Portál veřejné správy

Zápis OV436652-130920

Obchodní jménoBestsport Services, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO24215171
SídloPraha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00
Publikováno20. 09. 2013
Značka OVOV436652-130920
VALNÁ HROMADA; Bestsport Services, a.s. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17877 (dále jen »Společnost«) tímto svolává na základě žádosti akcionářů Společnosti - Moranda, a.s., IČ: 28171934, se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 00 a KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED, založené podle práva Kyperské republiky, se sídlem Alasias 8, Christodoulides Building, P.C. 3095 Limassol, Kyperská republika, registrační číslo HE 179840, ze dne 13. září 2013 v souladu s ustanovením § 181 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »obchodní zákoník«), a stanovami Společnosti, mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 8. října 2013 od 13 hodin v sídle Společnosti na výše uvedené adrese. Program mimořádné valné hromady: 1. Zahájení mimořádné valné hromady Společnosti a prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti; 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); 3. Přijetí změny stanov Společnosti; 4. Odvolání Ing. Roberta Schaffera, JUDr. Tomáše Porupky a Mgr. Michaely Šurmanové z funkce členů představenstva Společnosti; 5. Odvolání Ing. Richarda Benýška, Ing. Aleše Minxe a JUDr. Ing. Zdeňka Ertla z funkce členů dozorčí rady Společnosti; 6. Volba Mgr. Radka Dyntara, Ing. Pavla Šarocha, Ing. Richarda Benýška a Ing. Roberta Schaffera do funkce členů představenstva Společnosti; 7. Volba JUDr. Josefa Novotného, Mgr. Lubomíra Krále a JUDr. Ing. Zdeňka Ertla do funkce členů dozorčí rady Společnosti; 8. Schválení smluv o výkonu funkce a odměn Mgr. Radka Dyntara, Ing. Pavla Šarocha, Ing. Richarda Benýška a Ing. Roberta Schaffera, nově zvolených členů představenstva Společnosti; 9. Schválení smluv o výkonu funkce a odměn JUDr. Josefa Novotného, Mgr. Lubomíra Krále a JUDr. Ing. Zdeňka Ertla, nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti; 10. Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185, auditorem Společnosti; 11. Závěr mimořádné valné hromady Společnosti. K bodu 3: Přijetí změny stanov Společnosti Navrhují se zejména následující změny stanov: i) členy představenstva volí a odvolává valná hromada, ii) valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady a rozhoduje o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o plnění podle § 66 odst. 3 obchodního zákoníku, iii) představenstvo má 4 členy, iv) je volen předseda a místopředseda představenstva, v) v případě rovnosti hlasů nemá žádný ze členů představenstva rozhodující hlas, vyjma případu rozhodování o jmenování předsedy nebo místopředsedy představenstva, kdy je v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas toho člena představenstva, který je do dané funkce navrhován, vi) je volen předseda a místopředseda dozorčí rady, vii) jménem společnosti jednají vždy: a) předseda představenstva a místopředseda představenstva společně; nebo b) předseda představenstva společně se dvěma členy představenstva; nebo c) místopředseda představenstva společně se dvěma členy představenstva; nebo d) společně všichni členové představenstva, viii) nejpozději do 6 měsíců po uplynutí příslušného účetního období, představenstvo předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. K bodu 4: Odvolání Ing. Roberta Schaffera, JUDr. Tomáše Porupky a Mgr. Michaely Šurmanové z funkce členů představenstva Společnosti Valná hromada navrhuje odvolat i) Ing. Roberta Schaffera, dat. nar. 22. 1. 1976, bytem Praha 5-Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, PSČ 159 00, ii) JUDr. Tomáše Porupku, dat. nar. 12. 5. 1975, bytem Znojmo, Bratrstva 2118/47, PSČ 669 02 a iii) Mgr. Michaelu Šurmanovou, dat. nar. 26. 11. 1982, bytem Ivaň 89, PSČ 691 23 z funkce členů představenstva Společnosti. K bodu 5 Odvolání Ing. Richarda Benýška, Ing. Aleše Minxe a JUDr. Ing. Zdeňka Ertla z funkce členů dozorčí rady Společnosti Valná hromada navrhuje odvolat i) Ing. Richarda Benýška, dat. nar. 30. 9. 1967, bytem Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc, ii) Ing. Aleše Minxe, dat. nar. 25. 3. 1964, bytem Nad Hradním vodojemem 1083/43, Střešovice, 162 00 Praha a iii) JUDr. Ing. Zdeňka Ertla, dat. nar. 2. 10. 1955, bytem Dykova 960/4, Vinohrady, 101 00 Praha 10 z funkce členů dozorčí rady Společnosti. K bodu 6 Volba Mgr. Radka Dyntara, Ing. Pavla Šarocha, Ing. Richarda Benýška a Ing. Roberta Schaffera do funkce členů představenstva Společnosti Valná hromada navrhuje zvolit i) Mgr. Radka Dyntara, dat. nar. 15. 10. 1972, bytem Praha 4, Velké Kunratické 1322/45, PSČ 148 00, ii) Ing. Pavla Šarocha, dat. nar. 9. 7. 1970, bytem Nepálská 803/3, Vokovice, 160 00 Praha 6, iii) Ing. Richarda Benýška, dat. nar. 30. 9. 1967, bytem Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc a iv) Ing. Roberta Schaffera, dat. nar. 22. 1. 1976, bytem Praha 5-Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, PSČ 159 00 do funkce členů představenstva Společnosti. K bodu 7 Volba JUDr. Josefa Novotného, Mgr. Lubomíra Krále a JUDr. Ing. Zdeňka Ertla do funkce členů dozorčí rady Společnosti Valná hromada navrhuje zvolit i) JUDr. Josefa Novotného, dat. nar. 30. 5. 1952, bytem Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a ii) Mgr. Lubomíra Krále, dat. nar. 2. 12. 1972, bytem Praha 9-Horní Počernice, K Palečku 2711/36, PSČ 193 00 a iii) JUDr. Ing. Zdeňka Ertla, dat. nar. 2. 10. 1955, bytem Dykova 960/4, Vinohrady, 101 00 Praha 10 do funkce členů dozorčí rady Společnosti. K bodu 8 Schválení smluv o výkonu funkce a odměn Mgr. Radka Dyntara, Ing. Pavla Šarocha, Ing. Richarda Benýška a Ing. Roberta Schaffera, nově zvolených členů představenstva Společnosti Valná hromada navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a novými členy představenstva Společnosti: i) Mgr. Radka Dyntara, dat. nar. 15. 10. 1972, bytem Praha 4, Velké Kunratické 1322/45, PSČ 148 00, ii) Ing. Pavla Šarocha, dat. nar. 9. 7. 1970, bytem Nepálská 803/3, Vokovice, 160 00 Praha 6, a iii) Ing. Richarda Benýška, dat. nar. 30. 9. 1967, bytem Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc a iv) Ing. Roberta Schaffera, dat. nar. 22. 1. 1976, bytem Praha 5-Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, PSČ 159 00 a odměnu nových členů představenstva Společnosti uvedenou ve smlouvách o výkonu funkce. K bodu 9 Schválení smluv o výkonu funkce a odměn JUDr. Josefa Novotného, Mr. Lubomíra Krále a Mgr. Zdeňka Ertla, nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti Valná hromada navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a novými členy dozorčí rady Společnosti: i) JUDr. Josefem Novotným, dat. nar. 30. 5. 1952, bytem Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2 ii) Mgr. Lubomíra Krále, dat. nar. 2. 12. 1972, bytem Praha 9-Horní Počernice, K Palečku 2711/36, PSČ 193 00 a iii) JUDr. Ing. Zdeňka Ertla, dat. nar. 2. 10. 1955, bytem Dykova 960/4, Vinohrady, 101 00 Praha 10 a odměnu nových členů dozorčí rady Společnosti uvedenou ve smlouvách o výkonu funkce. K bodu 10 Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem Společnosti Navrhuje se určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185, auditorem Společnosti. Informace pro akcionáře Společnosti: Rozhodným dnem pro účast na této valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. rozhodný den je 1. říjen 2013. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní. Tato oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni a kdo tuto skutečnost na valné hromadě prokáže. Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou navíc písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Prezence akcionářů bude zahájena v 12.30 v místě konání valné hromady. Poučení: Návrh všech změn stanov Společnosti, resp. navrhované nové úplné znění stanov Společnosti, je k nahlédnutí v sídle Společnosti do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 13.00. Jako akcionář Společnosti máte právo do návrhu nahlédnout a/nebo si vyžádat zaslání kopie návrhu všech změn stanov Společnosti na svůj náklad a nebezpečí. --------------------------- ANNOUNCEMENT ON CONVOCATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Board of Directors of Bestsport Services, a.s., having its registered office at Prague 9, Českomoravská 2345/17, Postal Code 190 00, company identification number: 242 15 171, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, Entry No.: 17877 (hereinafter the »Company«), hereby convenes on the basis of the request of the shareholders of the Company - Moranda, a.s., identification number: 28171934, having its registered office at Evropská 2690/17, Praha 6, Postal Code: 160 00 and KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED, a company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, having its registered office at Alasias 8, Christodoulides Building, Postal Code 3095 Limassol, the Republic of Cyprus, registration number HE 179840, dated September 13, 2013, in accordance with Section 181 (2) of the Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code, as amended (hereinafter the »Commercial Code«) and with the Company's Articles of Association, the extraordinary General Meeting that shall take place on 8 October 2013 from 1 p.m. at registered office of the Company above. Agenda of the extraordinary General Meeting: 1. Opening of the extraordinary General Meeting and check of attendance of present shareholders, inspection of a quorum; 2. Election of bodies of the extraordinary General Meeting (chairman, minutes clerk, verifiers, person in charge of the votes counting); 3. Adoption of changes of the Company's Articles of Association; 4. Recall of Mr. Robert Schaffer, Mr. Tomáš Porupka and Mrs. Michaela Šurmanová from the function of the member of the Board of Directors of the Company; 5. Recall of Mr. Richard Benýšek, Mr. Aleš Minx and Mr. Zdeněk Ertl from the function of the member of the Supervisory Board of the Company; 6. Election of Mr. Radek Dyntar, Mr. Pavel Šaroch, Mr. Richard Benýšek and Mr. Robert Schaffer as members of the Board of Directors of the Company; 7. Election of Mr. Josef Novotný, Mr. Lubomír Král and Mr. Zdeněk Ertl as members of the Supervisory Board of the Company; 8. Approval of agreements on performance of the office concluded with new Board of Directors members - Mr. Radek Dyntar, Mr. Pavel Šaroch, Mr. Richard Benýšek and Mr. Robert Schaffer and their remuneration; 9. Approval of agreements on performance of the office concluded with new Supervisory Board members - Mr. Josef Novotný, Mr. Lubomír Král and Mr. Zdeněk Ertl and their remuneration; 10. Appointment of KPMG Česká republika Audit, s.r.o., company identification number: 496 19 187, having its registered office at Prague 8, Pobřežní 1a, Postal Code 186 00 registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section C, Entry No.: 24185 as the Auditor of the Company; 11. Closing of the extraordinary General Meeting. Ad item 3: Adoption of changes of the Company's Articles of Association In particular the following changes of Articles of Association are proposed: i) members of the Board of Directors are elected and recalled by the General Meeting, ii) the General Meeting approves agreements on performance of the office with members of the Board of Directors and Supervisory Board and decides on remuneration of the members of the Board of Directors and Supervisory Board and on performance in accordance with Section 66 (3) of the Commercial Code, iii) the Board of Directors has 4 members, iv) the Chairman and Vice-chairman of the Board of Directors are elected, v) in case of equal number of the votes, no member of the Board of Directors has the decisive vote with the exception of the case when the Chairman and Vice-chairman of the Board of Directors are elected when in cases of equal number of the votes the member of the Board of Directors who is proposed to be the Chairman or Vice-chairman has the decisive vote, vi) the Chairman and Vice-chairman of the Supervisory Board are elected, vii) acting on behalf of the company: a) Chairman of the Board of Directors and Vice-chairman of the Board of Directors together; or b) Chairman of the Board of Directors together with two members of the Board of Directors; or c) Vice-chairman of the Board of Directors together with two members of the Board of Directors; or d) all the members of the Board of Directors together, viii) the Board of Directors shall present the report on the business activity of the Company and the state of its assets 6 months after the end of respective accounting period at the lates Ad item 4 Recall of Mr. Robert Schaffer, Mr. Tomáš Porupka and Mrs. Michaela Šurmanová from the function of the member of the Board of Directors of the Company The recall of i) Mr. Robert Schaffer, born on 22. 1. 1976, residing at Prague 5-Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, Postal Code 159 00, ii) Mr. Tomáš Porupka, born on 12. 5. 1975, residing at Znojmo, Bratrstva 2118/47, Postal Code 669 02 and iii) Mrs. Michaela Šurmanová, born on 26. 11. 1982, residing at Ivaň 89, Postal Code 691 23 from the function of member of the Board of Directors of the Company is proposed. Ad item 5 Recall of Mr. Richard Benýšek, Mr. Aleš Minx and Mr. Zdeněk Ertl from the function of the member of the Supervisory Board of the Company The recall of i) Mr. Richard Benýšek, born on 30. 9. 1967, residing at Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc, ii) Mr. Aleš Minx, born on 25. 3. 1964, residing at Nad Hradním vodojemem 1083/43, Střešovice, 162 00 Prague and iii) Mr. Zdeněk Ertl, born on 2. 10. 1955, residing at Dykova 960/4, Vinohrady, 101 00 Prague 10 from the function of member of Supervisory Board of the Company is proposed. Ad item 6 Election of Mr. Radek Dyntar, Mr. Pavel Šaroch, Mr. Richard Benýšek and Mr. Robert Schaffer as members of the Board of Directors of the Company The election of i) Mr. Radek Dyntar, born on 15. 10. 1972, residing at Prague 4, Velké Kunratické 1322/45, Postal Code 148 00, ii) Mr. Pavel Šaroch, born on 9. 7. 1970, residing at Nepálská 803/3, Vokovice, 160 00 Prague 6, iii) Mr. Richard Benýšek, born on 30. 9. 1967, residing at Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc and iv) Mr. Robert Schaffer, born on 22. 1. 1976, residing at Prague 5-Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, Postal Code 159 00 as the new Board of Directors members of the Company is proposed. Ad item 7 Election of Mr. Josef Novotný, Mr. Lubomír Král and Mr. Zdeněk Ertl as members of the Supervisory Board of the Company The election of i) Mr. Josef Novotný, born on 30. 5. 1952, residing at Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Prague 2, ii) Mr. Lubomír Král, born on 2. 12. 1972, residing at Prague 9-Horní Počernice, K Palečku 2711/36, Postal Code 193 00 and iii) Mr. Zdeněk Ertl, born on 2. 10. 1955, residing at Dykova 960/4, Vinohrady, 101 00 Prague 10, as the new Supervisory Board members of the Company is proposed. Ad item 8 Approval of agreements on performance of the office concluded with new Board of Directors members - Mr. Radek Dyntar, Mr. Pavel Šaroch, Mr. Richard Benýšek and Mr. Robert Schaffer and their remuneration The approval of agreements on performance of the office concluded with new Board of Directors members i) Mr. Radek Dyntar, born on 15. 10. 1972, residing at Prague 4, Velké Kunratické 1322/45, Postal Code 148 00, ii) Mr. Pavel Šaroch, born on 9. 7. 1970, residing at Nepálská 803/3, Vokovice, 160 00 Prague 6, and iii) Mr. Richard Benýšek, born on 30. 9. 1967, residing at Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc and iv) Mr. Robert Schaffer, born on 22. 1. 1976, residing at Prague 5- -Velká Chuchle, U Bažantice 411/9, Postal Code 159 00 and their remuneration stated in the agreements on performance of the office. Ad item 9 Approval of agreements on performance of the office concluded with new Supervisory Board members - Mr. Josef Novotný, Mr. Lubomír Král and Mr. Zdeněk Ertl and their remuneration The approval of agreements on performance of the office concluded with new Supervisory Board members i) Mr. Josef Novotný, born on 30. 5. 1952, residing at Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Prague 2 ii) Mr. Lubomír Král, born on 2. 12. 1972, residing at Prague 9-Horní Počernice, K Palečku 2711/36, Postal Code 193 00 and iii) Mr. Zdeněk Ertl, born on 2. 10. 1955, residing at Dykova 960/4, Vinohrady, 101 00 Prague 10 and their remuneration stated in the agreements on performance of the office. Ad item 10 Appointment of KPMG Česká republika Audit, s.r.o. as the Auditor of the Company Appointment of KPMG Česká republika Audit, s.r.o., company identification number: 496 19 187, having its registered office at Prague 8, Pobřežní 1a, Postal Code 186 00 registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section C, Entry No.: 24185 as the Auditor of the Company is proposed. Information for the Company's shareholders: The decisive day for participating at this General Meeting is the seventh day preceding the day of the General Meeting, i.e. the decisive day is 1 October 2013. The decisive date is relevant for the determination of those persons, who are entitled to attend the General Meeting and to exercise shareholder rights, i.e. to vote at the General Meeting. Such an entitlement will only pertain to persons who were so authorized as of the decisive date and who can prove that at General Meeting. Shareholders - natural persons evidence their identity by a valid identification card. Persons acting on behalf of a legal entity shall present in addition to their identity card a document certifying the existence of the legal entity and their authorization to act on behalf of the legal entity. Representatives of the shareholders will present written power of attorney, which will include information on the scope of the authorization and notarized signature of the principal. Attendance check of shareholders will begin at 12.30 at the place of the General Meeting's session. Instruction: The proposal on all changes to the Articles of Association of the Company is available for inspection in the registered office of the Company until the day of the General Meeting in working days from 9 am to 1 pm. You are entitled, as a shareholder of the Company, to inspect the proposal on all changes to the Articles of Association of the Company and/or request sending a copy of the proposal on all changes to the Articles of Association of the Company at your cost and risk. V/In Praze dne/on 18.9.2013 Jménem představenstva Společnosti/ On behalf of the Board of Directors of the Company Ing. Robert Schaffer předseda představenstva/Chairman of the Board of Directors Mgr. Michaela Šurmanová člen představenstva/Member of the Board of Directors OV436652-130920